Dorothy May GRAEME - Page 36
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAN HOUSE PUBLISHERS LIMITED | 11 déc. 2003 | 11 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LABURNUM HOUSE LIMITED | 11 déc. 2003 | 11 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GIRLINGS SERVICES LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CBS MANAGED PRINT LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LYNDEN LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BARBUR DEVELOPMENTS LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PHIL INGLIS PHOTOGRAPHY LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SPIRE CONSULTING LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AARDVARK SHIRTS LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE OLD COASTGUARD HOTEL LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LASERPIN LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BERNWELL CNC LIMITED | 10 déc. 2003 | 10 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TV FORMATS LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WESTWARD JOINERY LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
POWELL-CRAFT (RETAIL) LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MARINE CONSULTANCY LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PETER JAMES CONSULTANTS LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R.S.G. (ROCHDALE) LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PREMIER HAIR & BEAUTY SUPPLIES LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FGA CONSULTING LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ORCHARDCREST LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DAVE MARTON RACING SERVICES LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KFT CIVIL ENGINEERING SERVICES LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
N. SHEPHERD ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MMP (ANGLIA) LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JPC BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | 09 déc. 2003 | 09 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J M HAIRDRESSING LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TONY MORRIS LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CIRCLE RED PROPERTIES LIMITED | 23 sept. 2003 | 05 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEIGER UK LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE FRENCH DELI (STOURBRIDGE) LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROSEWOOD PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P HUNT CONSULTANCY LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRIDGNORTH QUALITY ASSISTANCE LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BARRY MATTHEWS SCHOOL OF MOTORING LIMITED | 05 déc. 2003 | 05 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0