Dorothy May GRAEME - Page 253
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALCON ELECTRICAL WHOLESALERS LIMITED | 13 févr. 1995 | 16 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOWN & COUNTRY CARS (KENT) LIMITED | 15 févr. 1995 | 15 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PHOENIX SELECT FOOD INGREDIENTS LIMITED | 15 févr. 1995 | 15 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TARIZZO LIMITED | 10 févr. 1995 | 14 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRIANCO PERSONNEL SERVICES LIMITED | 14 févr. 1995 | 14 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INTERPLANDATA LIMITED | 10 févr. 1995 | 13 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OLDBURY PROPERTIES LIMITED | 20 janv. 1995 | 13 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JAMES ARMSTRONG CONTRACTORS LIMITED | 10 févr. 1995 | 10 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KENSINGTONGROVE LIMITED | 07 févr. 1995 | 10 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THERMOLINK LIMITED | 01 févr. 1995 | 10 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WELLWAY PHARMACY LIMITED | 09 févr. 1995 | 09 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SANDAFLOOR (1995) LIMITED | 09 févr. 1995 | 09 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
B. & S. INVESTMENTS (MANCHESTER) LIMITED | 23 janv. 1995 | 08 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ZERO BALANCE LIMITED | 17 janv. 1995 | 07 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INTO THE WEST LIMITED | 06 févr. 1995 | 06 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RADIOLINK LIMITED | 30 janv. 1995 | 06 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CURSORTEK LIMITED | 20 janv. 1995 | 03 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JUBILEEBAY LIMITED | 09 janv. 1995 | 03 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SILK OIL LIMITED | 03 févr. 1995 | 03 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PICTUREPARLOUR LIMITED | 09 janv. 1995 | 03 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MARIO DESIGNS LIMITED | 02 févr. 1995 | 02 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KEVIN JORDAN LIMITED | 01 févr. 1995 | 01 févr. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OLYMPIC SIMULATION LIMITED | 01 févr. 1995 | 01 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OLYMPIC ROADSHOWS LIMITED | 01 févr. 1995 | 01 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRIDENT MEDICAL SERVICES LIMITED | 01 févr. 1995 | 01 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PARADISEHOMES LIMITED | 20 janv. 1995 | 01 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INTROGROUP LIMITED | 30 janv. 1995 | 30 janv. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RAPID CITY LIMITED | 27 janv. 1995 | 27 janv. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KANNONTEK LIMITED | 09 janv. 1995 | 27 janv. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORDICMOUNT LIMITED | 23 déc. 1994 | 27 janv. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BOWIE LOCKWOOD STRUCTURES LIMITED | 25 janv. 1995 | 25 janv. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MARKAD LIMITED | 23 janv. 1995 | 23 janv. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SMITH TAYLOR NATURAL PRODUCTS LIMITED | 23 janv. 1995 | 23 janv. 1995 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FENTONWHARFE LIMITED | 03 janv. 1995 | 23 janv. 1995 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALLOY MASTERS LIMITED | 20 janv. 1995 | 20 janv. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0