Dorothy May GRAEME - Page 53
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADSTAIRS TANDOORI LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M K SOFT DRINKS LIMITED | 06 août 2003 | 06 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BUSINESS DYNAMICS (UK) LIMITED | 06 août 2003 | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ESTON PLUMBING & HEATING LIMITED | 18 juil. 2003 | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STEPHEN G. WEBB LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROSELINK LIMITED | 19 juil. 2003 | 04 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
T.T. SERVICES (ST. IVES) LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P&P CONSTRUCTION LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WLOCH ANALYTICS LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROBERTS MEDICO LEGAL SERVICES LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAG WEALTH MANAGEMENT LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OUTDOOR PARTNERS LIMITED | 01 juin 2003 | 31 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
POKER SUPPLIES LTD | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CRESCENT BUILDING SUPPLIES (RUISLIP) LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROSENDALE PROPERTY SERVICES LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROBSONS ACCOUNTANTS LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NO ENTRY ALARMS LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PERSONAL INVESTMENT PARTNERSHIP LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOHN MASTERS ASSOCIATES LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SUBITOEURO LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DRYLAND & WYKES ACCOUNTANTS LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE NORTHERN ART SHOW LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRAYS ELECTRICAL LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ERLESCOTE LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LEIGH PETTITT LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PHILLIPS & STUBBS LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
T DYSAK LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GREEN LANE CONSTRUCTION LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THOMAS TRAVEL LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HORSHAM & CRAWLEY CARE LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A WORLD OF SPORT & LEISURE LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SPECTRUM FINANCIAL PLANNING LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ANDY HILL (MILKMAN) LIMITED | 30 juin 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EVERSHINE ASSOCIATES LIMITED | 25 juin 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P & S MCGOWAN (BUILDERS) LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0