Dorothy May GRAEME - Page 94
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN KENDRICK CONSTRUCTION LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONCEPT CONSTRUCTION (EVANS) LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOPFLIGHT DEVELOPMENTS LIMITED | 30 sept. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D M MORGAN & CO. LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.C. THOMPSON & SONS LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SPRING HEATING & PLUMBING LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRUNDON MARINE LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FINE FINISH (TAPING AND JOINTING) LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SUPERIOR CLEANING SOLUTIONS LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TREVOR HARWOOD COMPLIANCE SERVICES LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DOMESTIC & COMMERCIAL SERVICES LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KDT PRODUCTIONS LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STROOD MOTOR COMPANY LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STABLE ASSETS LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PDS TRAINING LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CITYDRIVE (UK) LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAPITAL LIMO LIMITED | 06 nov. 2002 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOPFLIGHT ASSOCIATES LIMITED | 30 août 2002 | 06 nov. 2002 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FLEDGELINGS NURSERY SCHOOL LIMITED | 05 nov. 2002 | 05 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RAYNOR TOOL SERVICES LIMITED | 05 nov. 2002 | 05 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHRIS NOBLE LTD | 05 nov. 2002 | 05 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MEARS LIFETIME HOMES LIMITED | 05 nov. 2002 | 05 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.C.J. THOMPSON & CO LTD | 28 oct. 2002 | 05 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SHU CONCEPT LIMITED | 04 nov. 2002 | 04 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHITEHOUSE TAVERNS LIMITED | 04 nov. 2002 | 04 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONTROL CONSULTANCY LIMITED | 01 nov. 2002 | 01 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R C TROTMAN LIMITED | 01 nov. 2002 | 01 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ASHMAN CONSULTING LIMITED | 01 nov. 2002 | 01 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BAKES ROOFING LIMITED | 01 nov. 2002 | 01 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AMBERVALE ESTATES LIMITED | 09 oct. 2002 | 01 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BLUE HERON PROPERTIES LIMITED | 01 nov. 2002 | 01 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PETER WALKER ENGINEERING LIMITED | 31 oct. 2002 | 31 oct. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALCERETA LIMITED | 31 oct. 2002 | 31 oct. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OPALSTAR DESIGNS LIMITED | 28 oct. 2002 | 31 oct. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HAWKINS & SHEPHERD LIMITED | 30 oct. 2002 | 30 oct. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0