Dorothy May GRAEME - Page 148
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORGANS WEDDING CARS (SUB-CONTRACTS) LIMITED | 06 mars 2001 | 06 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WINSTER PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 06 mars 2001 | 06 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INNOVATIVE CHANGE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 06 mars 2001 | 06 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FARNLEY ESTATES (CORBRIDGE) LIMITED | 06 mars 2001 | 06 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BEST CONTRACT CLEANING LIMITED | 06 mars 2001 | 06 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MIKE HOGARTH LIMITED | 05 mars 2001 | 05 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NEWARK COMMERCIAL LIMITED | 05 mars 2001 | 05 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CATESBY ESTATES (HAWTON) LIMITED | 05 mars 2001 | 05 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
URBAN&CIVIC MIDDLEBECK LIMITED | 05 mars 2001 | 05 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FG SPRINKLER SERVICES LIMITED | 05 mars 2001 | 05 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HOPES GROVE NURSERIES (NATIVE PLANTS) LIMITED | 02 mars 2001 | 02 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TGC INTERNATIONAL LIMITED | 02 mars 2001 | 02 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UPPERCLASS MANAGEMENT LIMITED | 09 févr. 2001 | 02 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JONES COMPUTER CONSULTANTS LIMITED | 01 mars 2001 | 01 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A.B. ROOMS & SON LIMITED | 18 déc. 2000 | 28 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FOXGLOVE MARKETING LIMITED | 22 déc. 2000 | 28 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ELSHAMMA CORPORATION LIMITED | 12 déc. 2000 | 28 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.C. HANDRAILS AND IRONWORK PARTS LIMITED | 27 févr. 2001 | 27 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
VENTURE ASPECTS LIMITED | 28 déc. 2000 | 27 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ECOVITA LIMITED | 27 févr. 2001 | 27 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CFI LABELS & SYSTEMS LIMITED | 27 févr. 2001 | 27 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORFRIDGE LIMITED | 12 déc. 2000 | 27 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
1STOP-HOLDINGS LIMITED | 26 févr. 2001 | 26 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ECO-LIBRIUM SOLUTIONS LIMITED | 26 févr. 2001 | 26 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WATERTIGHT PIPEWORK LIMITED | 23 févr. 2001 | 23 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
REVELAN ESTATES (HARBORNE) LIMITED | 23 févr. 2001 | 23 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
POLO EVENTS TEAM LIMITED | 23 févr. 2001 | 23 févr. 2001 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOPCARS LIMITED | 22 févr. 2001 | 22 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HAMLET CATERING LIMITED | 11 déc. 2000 | 22 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DIAMOND ANIMAL FEEDS LIMITED | 22 févr. 2001 | 22 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LONDON HOSPITALITY LIMITED | 22 févr. 2001 | 22 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADDERSTONE (210) LIMITED | 21 févr. 2001 | 21 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOP FLITE SCAFFOLDING LIMITED | 21 févr. 2001 | 21 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A.R.L. RENOVATIONS LIMITED | 20 févr. 2001 | 20 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BAKER BEAUMONT LIMITED | 20 févr. 2001 | 20 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0