Dorothy May GRAEME - Page 140
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTGAGE FUNDING (HAMPSHIRE) LIMITED | 18 juin 2001 | 18 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROJECT SERVICES (UPMINSTER) LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LENDEL PAVING LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE CROWN SPA LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
C.L. POUNDER LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
T A SERVICES LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROY WEATHERILL (MARINE CONSULTANCY) LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S H COX LIMITED | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LIMA (INTERNATIONAL) LTD | 14 juin 2001 | 14 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRINT SERVICES (UK) LIMITED | 12 juin 2001 | 12 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHRIS NICHOLLS MOTORS LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
8TH WONDER ENTERPRISES LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUSTIN & ROSS SERIOUS ENTERPRISES LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DOWN-A-SIZE LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOWPATH LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WORXSAFE LIMITED | 11 juin 2001 | 11 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ORCHARDVIEW ENTERPRISES LIMITED | 29 mai 2001 | 08 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FEE-ONLY PLANNING LIMITED | 07 juin 2001 | 07 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COPPERFIELD MARKETING LIMITED | 25 avr. 2001 | 07 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHRIS RICHES LIMITED | 06 juin 2001 | 06 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TUDOR PARK RECRUITMENT CONSULTANCY LIMITED | 06 juin 2001 | 06 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WILLOWPOINT PROPERTIES LIMITED | 30 avr. 2001 | 06 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INFLUENCE APPAREL LIMITED | 20 mars 2001 | 06 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GREENGRASS DEVELOPMENTS LIMITED | 27 avr. 2001 | 05 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AVERY ROSE DECORATIONS LTD | 10 mai 2000 | 04 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STAR BRANDS LIMITED | 19 mars 2001 | 01 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OPTIDATA TECHNOLOGIES LIMITED | 01 juin 2001 | 01 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J S METALS LIMITED | 01 juin 2001 | 01 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
YACHT CLAIMS LIMITED | 01 juin 2001 | 01 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ASHURST RESIDENTIAL CARE LIMITED | 01 juin 2001 | 01 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OUSETECH LIMITED | 31 mai 2001 | 31 mai 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CULF DEVELOPMENTS LIMITED | 31 mai 2001 | 31 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ASLA TRAVEL LTD | 30 mai 2001 | 30 mai 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SMILING FACES LIMITED | 30 mai 2001 | 30 mai 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EAST PHOTOGRAPHIC LIMITED | 30 mai 2001 | 30 mai 2001 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0