Dorothy May GRAEME - Page 61
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTHERN FOUNDATIONS LIMITED | 08 avr. 2003 | 09 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WELLINGTON DOWNE LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
POPLAR BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BLACKTHORN WORKSHOP LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G & C COACHWORKS LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MERRYVALE SYSTEMS LIMITED | 03 avr. 2003 | 06 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MCMANN ASSOCIATES LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FARR & NEAR LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S R H ELECTRICAL LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NASH HARVEY SECRETARIAL SERVICES LTD | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BANLON LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BARNARD & SON (PLUMBING & HEATING) LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
4WARD TRAVEL LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RADIOTECHNICA LIMITED | 06 juin 2003 | 06 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TEA DIRECT LTD | 05 juin 2003 | 05 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GARY TSANG LIMITED | 05 juin 2003 | 05 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OAKSIDE CREATIONS LIMITED | 03 avr. 2003 | 05 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LOTUS DESIGN & PRINT LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE ANTIQUE WATCH COMPANY LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RN ROOFING LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRAEME N RICHARDSON IFA LIMITED | 03 avr. 2003 | 04 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOHN NANKERVIS & SON LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CS & TP CONSULTANCY LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE CONSERVATORY FACTORY (YORKSHIRE) LIMITED | 04 juin 2003 | 04 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHITECREST INVESTMENTS LIMITED | 08 avr. 2003 | 03 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHAIRMANS CLUB LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FORVAN HOLDINGS LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J. BULCOCK CONSULTANCY LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLASH LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R. HUNTER PROPERTY LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ASTER'OB LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ONLY PUBS SERVICES LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CEDAR ASSOCIATES (SE) LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NTC WHOLESALE LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRISTOL IMPORTS DIRECT LIMITED | 02 juin 2003 | 02 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0