Dorothy May GRAEME - Page 54
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANSOM WEY CONSTRUCTION LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G.A.R. SHIP LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHARMINGCARL LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PETER WOOD GAS INSTALLATIONS LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COX & SONS CONSTRUCTION LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WILLIAM J RILEY LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LETS PARTY & LETS DANCE LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DALE INSULATION SERVICES LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MICHAEL BROWN PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M.T.K. FABRICATIONS LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONSUMER BRANDS LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A B CORNUCOPIA LTD | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
VALENTINE DESIGNS LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M J H (JOINERS) LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OWEN & HARRISON LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SIMON N DELLER LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAIN SAUCE PRODUCTIONS LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PLUS PUBLISHING SERVICES LIMITED | 12 mai 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AZZURRO ENTERPRISES LIMITED | 24 juil. 2003 | 24 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SILK MOTORS LIMITED | 24 juil. 2003 | 24 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LUBI LU LIMITED | 09 mai 2003 | 24 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FIRGROVE CONSTRUCTION LIMITED | 09 mai 2003 | 24 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SENWOD CONTRACTING LIMITED | 23 juil. 2003 | 23 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GALLOWAY ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED | 23 juil. 2003 | 23 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRAINGER PLANNING ASSOCIATES LIMITED | 23 juil. 2003 | 23 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RICHBOROUGH TRANSPORT LIMITED | 23 juil. 2003 | 23 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
POPE'S CORNER MARINA LIMITED | 23 juil. 2003 | 23 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAIDSTONE AFP LIMITED | 07 mai 2003 | 23 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SYSTEMASTIC LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WGC LANDSCAPES LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROBINSON PLUMBING & HEATING SUPPLIES LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BACKLIGHT PICTURES LTD | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JBC COMPUTER SYSTEMS (COVENTRY) LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CENTURY UK LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GILHAMS HOLDINGS LIMITED | 22 juil. 2003 | 22 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0