Dorothy May GRAEME - Page 236
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER PRIMARYCARE LIMITED | 25 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRADLEY AND LENG LTD. | 25 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RELAY RECRUITMENT LIMITED | 12 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AIRSPACE SERVICES LIMITED | 25 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SIMPLY BETTER SERVICES LIMITED | 25 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COMMERCIAL CONSTRUCTION & ASSOCIATED SERVICES LIMITED | 25 juil. 1996 | 25 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JBL CONTRACTS LIMITED | 10 juil. 1996 | 24 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STRANDBAY LIMITED | 08 févr. 1996 | 24 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRINT UK (MANSFIELD) LIMITED | 22 juil. 1996 | 22 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHITE ROSE NATURAL SPRING WATER LIMITED | 22 juil. 1996 | 22 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DERNIER PROPERTIES LIMITED | 22 juil. 1996 | 22 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DECRA LED LIMITED | 19 juil. 1996 | 19 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ILLUMINATIONS FILMS LIMITED | 18 juil. 1996 | 18 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PHOENIX DISTRIBUTION AND EXPORT LIMITED | 18 juil. 1996 | 18 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LONG CLAWSON MEDICAL SERVICES LIMITED | 28 juin 1996 | 17 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRIFFITHS ENGINEERING LIMITED | 17 juil. 1996 | 17 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GARDINERS LIMITED | 17 juil. 1996 | 17 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MCCARTHY HOLDEN (FLEET) LIMITED | 05 juil. 1996 | 16 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUGUST.ONE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED | 12 juil. 1996 | 12 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TAYMAN ENGINEERING LIMITED | 12 juil. 1996 | 12 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THOMPSONS CIVIL ENGINEERING LTD | 12 juil. 1996 | 12 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLINICAL PSYCHOLOGICAL SERVICE: CENTRE OF ADVANCEMENT LIMITED | 12 juil. 1996 | 12 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BOXCLEAN SYSTEMS LIMITED | 12 juil. 1996 | 12 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRICKWOOD ESTATES LIMITED | 10 juil. 1996 | 10 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SCRIBBLERS DEN LIMITED | 10 juil. 1996 | 10 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SWANLAND SHIPPING LIMITED | 10 juil. 1996 | 10 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R B AND H M CARR & SONS LIMITED | 08 juil. 1996 | 08 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S.A.P. CONSTRUCTION LIMITED | 05 juil. 1996 | 05 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INITIALSOLUTIONS LIMITED | 26 juin 1996 | 05 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
C. BRITON LIMITED | 05 juil. 1996 | 05 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
1ST CHARTER LIMITED | 05 juil. 1996 | 05 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ESTATE SECURITY SOUTHERN LIMITED | 21 juin 1996 | 05 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HORIZONCROWN LIMITED | 21 juin 1996 | 05 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HILTONDELL LIMITED | 21 juin 1996 | 03 juil. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ANDREW JAMES LIMITED | 02 juil. 1996 | 02 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0