BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 105
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
DUFFY DISTRIBUTION LIMITED | 03. Feb. 1994 | 03. Feb. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MCKENNA DEMOLITION (KENT) LIMITED | 03. Feb. 1994 | 03. Feb. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NATURALBLOCK LIMITED | 23. Aug. 1993 | 03. Feb. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EXTRASCAN LIMITED | 21. Jan. 1994 | 31. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HUDDERSFIELD TERRAZZO & MARBLE TILING CO. LIMITED | 31. Jan. 1994 | 31. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FIRMCENTRE LIMITED | 15. Apr. 1993 | 31. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOUTH BUCKS HOSPICE (TRADING COMPANY) LIMITED | 27. Jan. 1994 | 27. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GURUTEC LIMITED | 27. Jan. 1994 | 27. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
F.A. RICHARD & CO LIMITED | 27. Jan. 1994 | 27. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FUNCTION PLAN LIMITED | 29. Sept. 1993 | 27. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ULTIMATE GRAPHICS LIMITED | 27. Jan. 1994 | 27. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STANLEY SOFTWARE LIMITED | 27. Jan. 1994 | 27. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SWIFT DENTAL LABORATORY LIMITED | 07. Dez. 1993 | 24. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D T L REFRIGERATION LIMITED | 29. Sept. 1993 | 24. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
XERORISK LIMITED | 09. Juni 1993 | 24. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RAPIDSOURCE LIMITED | 22. Jan. 1993 | 22. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIVEBRANCH LIMITED | 01. Feb. 1994 | 21. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NORTH COAST INDUSTRIES UK LIMITED | 21. Jan. 1994 | 21. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONTRACTISSUE LIMITED | 24. Dez. 1993 | 21. Jan. 1994 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SCOTPLAS LIMITED | 23. Dez. 1993 | 20. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R.D.B. DEVELOPMENTS LIMITED | 28. Sept. 1993 | 20. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AXIOM SOFTWARE LIMITED | 19. Jan. 1994 | 19. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE SNOWBOARD ASYLUM LIMITED | 19. Jan. 1994 | 19. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SAM FIBRES LIMITED | 19. Jan. 1994 | 19. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STYAL MANAGEMENT LTD | 17. Dez. 1993 | 19. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DIRECT LAW ACCIDENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 20. Sept. 1993 | 18. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MORSON (RBS) LIMITED | 13. Jan. 1994 | 18. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LANGDALE COMMUNICATIONS LIMITED | 06. Sept. 1993 | 17. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRIDGESHIRE PACKAGING LIMITED | 15. Jan. 1993 | 15. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SCIENTIFIC ANALYSIS INSTRUMENTS LIMITED | 14. Jan. 1994 | 14. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R P VALVES LIMITED | 14. Jan. 1994 | 14. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INDEPENDENT DEVELOPMENTS LIMITED | 14. Jan. 1994 | 14. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AGRIVERT LIMITED | 06. Jan. 1994 | 13. Jan. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLUTTON ESTATES LIMITED | 13. Jan. 1994 | 13. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AMEC MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 13. Jan. 1994 | 13. Jan. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0