BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 16
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| MISTRAL ENERGY PRODUCTS LIMITED | 25. Juni 1998 | 27. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MEADOW CHERRY LIMITED | 25. Juni 1998 | 03. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOHN C BENJAMIN LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LEMON SQUEEZY LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EPOCH 2000 LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GLA999 LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PARANOID? LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CROSSCARE LIMITED | 25. Juni 1998 | 17. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FRIARGATE FINANCIAL SOLUTIONS LTD | 25. Juni 1998 | 01. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CELLTECH BATTERY SALES & SERVICE LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| 1010 TAXIS LIMITED | 25. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| READYVALUE LIMITED | 25. Juni 1998 | 09. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FORMSCAN LIMITED | 25. Juni 1998 | 28. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| B & W DENTAL LABORATORIES LIMITED | 24. Juni 1998 | 24. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CROSBY'S LIMITED | 24. Juni 1998 | 24. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ELEGANT HOMES (SOUTH WEST) LIMITED | 24. Juni 1998 | 24. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DATATRANS COMMUNICATIONS LIMITED | 23. Juni 1998 | 23. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WYMONDHAM PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 23. Juni 1998 | 23. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HEALTH RACK LIMITED | 23. Juni 1998 | 23. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| REID PROPERTY SERVICES LIMITED | 23. Juni 1998 | 23. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| S.P.PHARMACIES LIMITED | 22. Juni 1998 | 22. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HAYDEN COURT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 22. Juni 1998 | 22. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MULTI-PLY COMPONENTS LIMITED | 19. Juni 1998 | 19. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE TRAINING DEPT. LTD | 18. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STIRLING INDUSTRIALS LIMITED | 18. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FEATHER & FIN LIMITED | 18. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOLLY DESIGNS LIMITED | 18. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ANCESTRAL WINDOWS & CONSERVATORIES LIMITED | 18. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DOVERHAY DEVELOPMENTS LTD | 17. Juni 1998 | 17. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALLIANCE PRESTIGE LIMITED | 17. Juni 1998 | 17. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOHN SCOTT BUILDERS (SOMERSET) LIMITED | 17. Juni 1998 | 17. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MILLENNIUM FORK TRUCKS LIMITED | 16. Juni 1998 | 16. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MARTIN FLITTON LIMITED | 16. Juni 1998 | 16. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ST. ENOCH PARTNERSHIP LIMITED | 16. Juni 1998 | 16. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BASEBAR LIMITED | 15. Juni 1998 | 02. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0