BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 66
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
NOZ-ALLS LIMITED | 16. Juli 1996 | 17. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FIRE EQUIPMENT SERVICES LIMITED | 16. Juli 1996 | 17. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOUNDFORMAT LIMITED | 13. Juni 1996 | 17. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ASAP LOGISTICS UK LIMITED | 15. Juli 1996 | 16. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MB AUTOMATION LIMITED | 15. Juli 1996 | 16. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PRIMARYSPACE LIMITED | 07. Juni 1996 | 16. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KENIRY CONTRACTS LIMITED | 15. Juli 1996 | 16. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAKELAND MANUFACTURING LIMITED | 24. Juni 1996 | 16. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NATURECLAIM LIMITED | 05. Juni 1996 | 15. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FILTER PUMP SERVICES LIMITED | 11. Juli 1996 | 12. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GENERALDIRECT LIMITED | 28. Juni 1996 | 12. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SPINKS SPEKS LIMITED | 10. Juli 1996 | 11. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GNOSALL HEALTH CARE LIMITED | 10. Juli 1996 | 11. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JENSEN DEVELOPMENTS LTD | 09. Juli 1996 | 10. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE SOURCE NETWORK (UK) LIMITED | 09. Juli 1996 | 10. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHOICECLAIM LIMITED | 06. März 1996 | 08. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AMERICAN LINE LIMITED | 04. Juli 1996 | 05. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FACILITIES CONTROL LIMITED | 04. Juli 1996 | 05. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ATROPOS LIMITED | 04. Juli 1996 | 05. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STATUSGAIN LIMITED | 14. Juni 1996 | 04. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ASTRON PACKAGING LIMITED | 02. Juli 1996 | 03. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SINO IONS LIMITED | 02. Juli 1996 | 03. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DIDSBURY PLANT HIRE LIMITED | 02. Juli 1996 | 03. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ATLAS HEALTH CONSULTANTS LIMITED | 02. Juli 1996 | 03. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
86 IVERSON ROAD LIMITED | 01. Juli 1996 | 02. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MAA SERVICES (UK) LTD | 01. Juli 1996 | 02. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CARR HOUSE BARN MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Juli 1996 | 01. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GASTECH INSTALLATIONS LIMITED | 28. Juni 1996 | 01. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FLANAGANS BARBER SHOP LIMITED | 14. Mai 1996 | 01. Juli 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
L.J. TIMBER (TREE SURGEONS) LIMITED | 25. Jan. 1996 | 01. Juli 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ECO TURF LIMITED | 02. Mai 1996 | 28. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TALENTCORE LIMITED | 30. Mai 1996 | 26. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D & C ENGINEERING LIMITED | 25. Juni 1996 | 26. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SAUNDERBIES LIMITED | 25. Juni 1996 | 26. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
P.A.G.E. ENTERPRISES LIMITED | 24. Juni 1996 | 25. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0