BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 40
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
P B LEAD PRODUCTS LIMITED | 19. Aug. 1997 | 19. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADAGIO CONSULTING LIMITED | 19. Aug. 1997 | 19. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GENUINECAUSE LIMITED | 19. Aug. 1997 | 08. Okt. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
229 MITCHAM LANE LIMITED | 19. Aug. 1997 | 19. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
E L BAILES (TECHNICAL SERVICES) LIMITED | 19. Aug. 1997 | 19. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ARESCO COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19. Aug. 1997 | 19. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SIGN RIBBONS (U.K.) LIMITED | 19. Aug. 1997 | 24. Sept. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RINGWAY ADVERTISING & MARKETING LIMITED | 18. Aug. 1997 | 18. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
35 ST. AUBYNS LIMITED | 18. Aug. 1997 | 18. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PPA SOFTWARE (UK) LIMITED | 18. Aug. 1997 | 18. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MEDMAS PROPERTIES LIMITED | 18. Aug. 1997 | 18. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REAL DEALS TRAVEL LIMITED | 18. Aug. 1997 | 18. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CTO LIGHTING LIMITED | 14. Aug. 1997 | 14. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADLIB DEVELOPMENTS LIMITED | 14. Aug. 1997 | 14. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KINGFISHER TRAINING & OFFICE SERVICES LIMITED | 14. Aug. 1997 | 14. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HOLMESDALE LTD | 13. Aug. 1997 | 13. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RUDDOCK BUSINESS SYSTEMS LIMITED | 13. Aug. 1997 | 13. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOTIONPOWER LIMITED | 13. Aug. 1997 | 08. Sept. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TIPLADY PROJECT SERVICES LIMITED | 13. Aug. 1997 | 13. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAR-KIT SERVICES LIMITED | 12. Aug. 1997 | 12. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PERFECT FINISH LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EASTERN SURVEILLANCE SERVICES LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
M D CONSTRUCTION (BRADFORD) LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SIDEY'S PROPERTIES LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAYPLAN LIMITED | 08. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
YORK WINDOWS LIMITED | 08. Aug. 1997 | 08. Aug. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAMEO FACIALS LIMITED | 07. Aug. 1997 | 20. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PUNCHINELLO LIMITED | 07. Aug. 1997 | 07. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VILLAGE LETTINGS LIMITED | 06. Aug. 1997 | 06. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIVEFRAME LIMITED | 06. Aug. 1997 | 16. Okt. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STRAND PROPERTIES LTD | 06. Aug. 1997 | 20. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CGL SOFTWARE LIMITED | 06. Aug. 1997 | 06. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PISCES PLASTICS LIMITED | 06. Aug. 1997 | 06. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REVERSAL COLOUR LIMITED | 05. Aug. 1997 | 05. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
IAN COX DESIGN LIMITED | 04. Aug. 1997 | 04. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0