BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 44
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
METRO INSPECTION SERVICES LIMITED | 22. Apr. 1997 | 03. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
3RD EYE SOLUTIONS LIMITED | 03. Juli 1997 | 03. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
F.P.T.M. LIMITED | 03. Juli 1997 | 03. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAMBRIDGE FILM & TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED | 03. Juli 1997 | 03. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HARGREAVES PROCESS SERVICES LIMITED | 03. Juli 1997 | 03. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AMACUS ADDED VALUE LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FRIENDSHIP MILL BEDS LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHARLES A. TOWLSON AND ASSOCIATES LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE GATE FILMS LIMITED | 01. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
METEOR ADVERTISING LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RICHARD FENN DESIGNS LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MIA FILMS & TELEVISION LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENDEAVOUR CHANDLERY LIMITED | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LISCHA LIMITED | 01. Juli 1997 | 01. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MSFP SOLUTIONS LIMITED | 01. Juli 1997 | 01. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WARD CONTRACT SERVICES LTD | 01. Juli 1997 | 01. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PIERRIS PROPERTIES LIMITED | 01. Juli 1997 | 01. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADVANCED MECHANICAL INSTALLATIONS LIMITED | 15. Apr. 1997 | 01. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
UNITMOVEMENTS LIMITED | 27. März 1997 | 30. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SMOOGRO ESTATES LIMITED | 30. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SITEPRINT LIMITED | 13. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MELBOURNE COMMERCIAL CENTRE COMPANY LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MURPHY ESTATES (RESIDENTIAL) LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R ETCHELLS & SONS LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NORTON ENGINEERING ANALYSIS LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GOLDROCK INVESTMENTS LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GENAMIK LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOUTH EASTERN CABLE CONTRACTORS LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MAINCOLOUR LIMITED | 29. Mai 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONTRACTCHOICE LIMITED | 23. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SAFETECH LTD | 26. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROJECT SURVEYING LIMITED | 25. Juni 1997 | 25. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LEICESTER TOOLING LIMITED | 06. Juni 1997 | 24. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GRIME-A-WAY SERVICES LIMITED | 22. Apr. 1997 | 24. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BONNETHILL DEVELOPMENTS LIMITED | 23. Juni 1997 | 23. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0