BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 44
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
GENAMIK LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOUTH EASTERN CABLE CONTRACTORS LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SAFETECH LTD | 26. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROJECT SURVEYING LIMITED | 25. Juni 1997 | 25. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONTRACTCHOICE LIMITED | 23. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SEATRACK LIMITED | 23. Juni 1997 | 10. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BONNETHILL DEVELOPMENTS LIMITED | 23. Juni 1997 | 23. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EARTH SHIFT LIMITED | 23. Juni 1997 | 04. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ONE VOICE MUSIC LIMITED | 23. Juni 1997 | 23. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STOP SEARCHING.COM LIMITED | 23. Juni 1997 | 08. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LINCOLN PROTEINS LIMITED | 20. Juni 1997 | 20. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EWHURST CONTROL SERVICES LIMITED | 20. Juni 1997 | 20. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TILETECH LIMITED | 20. Juni 1997 | 20. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R P B SITEXCEL LIMITED | 20. Juni 1997 | 20. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACCOUNTANCY BASED COMPUTING LIMITED | 19. Juni 1997 | 19. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SUTHERLAND EDUCATION LTD | 18. Juni 1997 | 18. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE HANCOCK PARTNERSHIP LIMITED | 17. Juni 1997 | 17. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLEE BECK (TECHNICAL SERVICES) LIMITED | 17. Juni 1997 | 17. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AJMD CONSULTING LTD | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MISSIONPHASE LIMITED | 13. Juni 1997 | 21. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FLINTNINE FASTENERS LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SITEPRINT LIMITED | 13. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SET MARKETING SERVICES LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACORN FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HERTSMERE BOROUGH FUNERAL & MEMORIAL SERVICES LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DAVE BARRON CARAVANS LIMITED | 12. Juni 1997 | 19. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WELLINGS GROUP LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
COBWEBS OF LOCKERBIE LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
S C S MAINTENANCE LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
G & B MCKIE ENGINEERING RESOURCES LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BERI MARKETING CONSULTANCY LIMITED | 11. Juni 1997 | 18. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALLWEATHER REFRIGERATION LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NINE THE FIRS PROPERTY MANAGEMENT CO. LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JACK MORTON EUROPE LIMITED | 10. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.D.G. HOME CENTER LIMITED | 10. Juni 1997 | 10. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0