BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 87
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTH CHESHIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 10. Mai 1995 | 11. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COMACC CONSULTANCY LIMITED | 10. Mai 1995 | 11. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| C A OBJECT TECHNOLOGY LTD | 10. Mai 1995 | 11. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GEM GARDENING LIMITED | 10. Mai 1995 | 11. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE MARGARET SHERRY COLLECTION LIMITED | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SELKIRK AND WESTMORELAND LIMITED | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WALLACE KENDRICK ASSOCIATES LTD | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PETER JACKSON & SONS LIMITED | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| C & C MELROSE LIMITED | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ESTATE AGENCY PROFESSIONALS LIMITED | 09. Mai 1995 | 10. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| YEOMAN CARE LIMITED | 05. Mai 1995 | 16. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| G.K. PARKER LIMITED | 05. Mai 1995 | 14. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MACRO GRAPHICS LIMITED | 05. Mai 1995 | 09. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GLASS HOUSES LIMITED | 05. Mai 1995 | 09. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ROZEL CONSULTING LIMITED | 05. Mai 1995 | 09. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GD ENTERPRISE LIMITED | 05. Mai 1995 | 19. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALEXANDER HARRIS (ALTRINCHAM) LIMITED | 05. Mai 1995 | 06. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SCM TURBOMOTIVE LIMITED | 05. Mai 1995 | 18. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COMMUNITY CAPITAL LIMITED | 03. Mai 1995 | 04. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ROLT MARKETING LIMITED | 02. Mai 1995 | 03. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MQM LTD | 28. Apr. 1995 | 01. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ARCHITECTURE IN GLASS LIMITED | 28. Apr. 1995 | 01. Mai 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MISSON PALLETS SERVICES LIMITED | 27. Apr. 1995 | 28. Apr. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SMARTCAP LIMITED | 27. Apr. 1995 | 01. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| D L R MARKETING LIMITED | 27. Apr. 1995 | 28. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NOLAN ENVIRONMENTAL LIMITED | 26. Apr. 1995 | 27. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A J C TECHNOLOGY LIMITED | 26. Apr. 1995 | 27. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LINEA CONSULTANTS LIMITED | 26. Apr. 1995 | 27. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THUNDERING SCRIBES LIMITED | 21. Apr. 1995 | 24. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FAZ (EUROPE) LIMITED | 21. Apr. 1995 | 12. Mai 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MEDICO LEGAL RECORDS LIMITED | 21. Apr. 1995 | 06. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INTERNATIONAL FOOD AND CHEMICALS LIMITED | 21. Apr. 1995 | 24. Apr. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| P F DAVENPORT (MUSIC) LIMITED | 21. Apr. 1995 | 24. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| M & S CAR SALES LIMITED | 21. Apr. 1995 | 24. Apr. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STANLEY COURT (MANCHESTER) MANAGEMENT CO LIMITED | 19. Apr. 1995 | 20. Apr. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0