BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 47
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
NORTH WEST CONTRACTING LIMITED | 16. Mai 1997 | 19. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KEY PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 16. Mai 1997 | 02. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
APOLLO ACCIDENT REPAIR GROUP LIMITED | 16. Mai 1997 | 16. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GREAT GIZMOS LIMITED | 15. Mai 1997 | 23. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAREHOME PAYROLLS LIMITED | 15. Mai 1997 | 15. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INSTANTCONCEPT LIMITED | 15. Mai 1997 | 11. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
YEOWARD SHIPPING LIMITED | 15. Mai 1997 | 04. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STAKEHOLDER PUBLICATIONS LIMITED | 15. Mai 1997 | 15. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THISTLE JOINERY & BUILDING SERVICES LIMITED | 15. Mai 1997 | 16. Mai 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DOWNEND FLOORING & TILING LIMITED | 15. Mai 1997 | 15. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
UKSS RENEWABLE ENERGY SERVICES LIMITED | 14. Mai 1997 | 20. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONSULT PF LIMITED | 14. Mai 1997 | 14. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D-TECH ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 14. Mai 1997 | 14. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STEMMER IMAGING LIMITED | 14. Mai 1997 | 21. Juli 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ROMTEK LIMITED | 14. Mai 1997 | 14. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JOHN LLOYDS KITCHEN ACCESSORIES LIMITED | 14. Mai 1997 | 14. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOYWEST HOLDINGS LIMITED | 13. Mai 1997 | 04. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VISUAL RECORD LIMITED | 13. Mai 1997 | 15. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AQUA TITE SERVICES LIMITED | 13. Mai 1997 | 13. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
APOLLO PRINT SERVICES (NORTH WEST) LIMITED | 13. Mai 1997 | 13. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D. V. COMMERCIALS LIMITED | 12. Mai 1997 | 13. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANDREW WILSON & CO LIMITED | 09. Mai 1997 | 09. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOTALCONTROL LIMITED | 09. Mai 1997 | 19. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHARLOTTES HOUSE LIMITED | 09. Mai 1997 | 09. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CERBERUS RECEIVABLES MANAGEMENT LIMITED | 09. Mai 1997 | 09. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALFA BRAVO LIMITED | 07. Mai 1997 | 07. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHOICENAME LIMITED | 07. Mai 1997 | 16. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EDWARD HITCHEN ASSOCIATES LIMITED | 07. Mai 1997 | 07. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE LITTLE M COMPANY LIMITED | 06. Mai 1997 | 15. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
W. BRACEGIRDLE & SONS LIMITED | 06. Mai 1997 | 07. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DRIVEFORM LIMITED | 06. Mai 1997 | 14. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VECTOR ANALYTIC LIMITED | 02. Mai 1997 | 06. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DESIGN STUFF LIMITED | 02. Mai 1997 | 06. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MEDI TALK LIMITED | 02. Mai 1997 | 06. Mai 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOORLAND SURGICAL SUPPLIES LIMITED | 02. Mai 1997 | 02. Mai 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0