BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 67
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
P.A.G.E. ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED | 24. Juni 1996 | 25. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KUB LIMITED | 24. Juni 1996 | 25. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TRUE PRECISION ENGINEERING LIMITED | 24. Juni 1996 | 25. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
P.A.G.E. GROUP (PETERBOROUGH) LIMITED | 21. Juni 1996 | 24. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BELL & CLEMENTS UNDERWRITING MANAGERS LIMITED | 18. Jan. 1996 | 24. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PICTURESOURCE LIMITED | 17. Mai 1996 | 21. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MASTERCORE LIMITED | 18. Apr. 1996 | 20. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GREEN PROPERTIES LIMITED | 18. Juni 1996 | 19. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J2 CONSULTING LIMITED | 26. März 1996 | 19. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DALROD (UK) LIMITED | 11. Apr. 1996 | 18. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BARKELEY MEDIA LIMITED | 12. Juni 1996 | 13. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SPORTAX LTD | 24. Mai 1996 | 13. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DURHAM STRUCTURES LIMITED | 13. Juni 1996 | 13. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FLEXICAT LIMITED | 12. Juni 1996 | 13. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ONE 2 ONE SYSTEMS LIMITED | 11. Juni 1996 | 12. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JETSKI SAFARIS LIMITED | 11. Juni 1996 | 12. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOTAL HERBAL CONFUSION LIMITED | 11. Juni 1996 | 12. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WOODCROFT HOLDINGS LIMITED | 22. Mai 1996 | 12. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SJB STEEL LIMITED | 07. Juni 1996 | 10. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MATTHEW STEELE LANDSCAPING LIMITED | 07. Juni 1996 | 10. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EUROPEAN EMC PRODUCTS LIMITED | 07. Juni 1996 | 10. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R. S. CONSTRUCTION LIMITED | 20. Mai 1996 | 10. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BIG "K" HALAL PRODUCTS LIMITED | 07. Juni 1996 | 10. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POINTCENTRE LIMITED | 30. Mai 1996 | 10. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PREMIERCODE LIMITED | 07. Mai 1996 | 10. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SHIRTS COMPANY LIMITED | 05. Juni 1996 | 06. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TML INTERNATIONAL LIMITED | 05. Juni 1996 | 06. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MET - CLAD CONTRACTS LIMITED | 12. Apr. 1996 | 05. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INFORMED CHOICE (UK) LIMITED | 04. Juni 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOBIT SOFTWARE LIMITED | 03. Juni 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WINNING LINE RETAIL LIMITED | 03. Juni 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHASE RUSSELL LIMITED | 01. Apr. 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RHINO DESIGN (MANCHESTER) LTD. | 03. Juni 1996 | 04. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLEAR MARKETING COMMUNICATIONS LIMITED | 16. Apr. 1996 | 04. Juni 1996 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PETER KELLY (G.B.) LIMITED | 30. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0