BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 67
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
TOBIT SOFTWARE LIMITED | 03. Juni 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WINNING LINE RETAIL LIMITED | 03. Juni 1996 | 05. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FRABAR ELECTRONICS (MELTON MOWBRAY) LIMITED | 30. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PETER KELLY (G.B.) LIMITED | 30. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TALENTCORE LIMITED | 30. Mai 1996 | 26. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SHEILA PANTRY ASSOCIATES LIMITED | 30. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.L.R. LIMITED | 30. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POINTCENTRE LIMITED | 30. Mai 1996 | 10. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CADFAN LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EUROFLO FLUID HANDLING LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KINGFORD LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TPS TRANSFERS LTD. | 29. Mai 1996 | 16. Aug. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
N.I. EUROPE LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R AND A OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIVE SUPPLY AND DESIGN LIMITED | 29. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
READ & ERRINGTON LIMITED | 24. Mai 1996 | 28. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SPORTAX LTD | 24. Mai 1996 | 13. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIVE SUPPLY AND DESIGN (C D M) LIMITED | 24. Mai 1996 | 28. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MATTMAN LIMITED | 24. Mai 1996 | 06. Sept. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ROSELEA DEVELOPMENTS LIMITED | 23. Mai 1996 | 24. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENDEAVOUR OIL & GAS LIMITED | 23. Mai 1996 | 24. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MINT APPAREL LIMITED | 22. Mai 1996 | 23. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WOODCROFT HOLDINGS LIMITED | 22. Mai 1996 | 12. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE LITTLE GREENE PAINT COMPANY LIMITED | 22. Mai 1996 | 23. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RICKARD LAZENBY AND CO. (LONDON) LIMITED | 22. Mai 1996 | 23. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SDS SUPPLIES LIMITED | 22. Mai 1996 | 29. Aug. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOULDING ENVIRONMENTAL LIMITED | 21. Mai 1996 | 22. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AMEC FOSTER WHEELER INTERNATIONAL LIMITED | 21. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NORWESTER LIMITED | 20. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TEXCO LIMITED | 20. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R. S. CONSTRUCTION LIMITED | 20. Mai 1996 | 10. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STONEHILL NURSERIES & GARDEN CENTRE LIMITED | 20. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
I T L IMPEX LIMITED | 17. Mai 1996 | 20. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WFCA INTEGRATED LIMITED | 17. Mai 1996 | 12. Aug. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PICTURESOURCE LIMITED | 17. Mai 1996 | 21. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0