BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 135
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
DUNSTERS FARM (HOLDINGS) LIMITED | 10. Juli 1991 | 10. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRIDGE CAR COMPANY LIMITED | 05. Juli 1991 | 05. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAM-FAB LIMITED | 05. Juli 1991 | 18. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MELLOR BEEF COMPANY LIMITED | 05. Juli 1991 | 26. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LONGRIDGE BEEF COMPANY LIMITED | 03. Juli 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FINCH ASSOCIATES LIMITED | 28. Juni 1991 | 31. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A T MOUNTFORD LIMITED | 28. Juni 1991 | 20. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INNERCODE LIMITED | 27. Juni 1991 | 16. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LINKDEAL LIMITED | 27. Juni 1991 | 09. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
UK RIGGING LTD | 27. Juni 1991 | 12. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SIMPLER SHOPPING LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHESTER INTERNATIONAL LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEE - SCAN LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MDF DESIGN LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEALERCAST LIMITED | 24. Juni 1991 | 20. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STAFFORD GLAZING SERVICES LIMITED | 24. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOTTLEWORTH BEEF COMPANY LIMITED | 24. Juni 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VENTUREPULSE LIMITED | 24. Juni 1991 | 15. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SPRINTDELIVER LIMITED | 24. Juni 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAN DO BUSINESS SERVICES LIMITED | 21. Juni 1991 | 21. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
QPC LIMITED | 20. Juni 1991 | 30. Jan. 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.N. FASHIONS LIMITED | 20. Juni 1991 | 20. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
READYEARN LIMITED | 20. Juni 1991 | 03. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE GRANARIES RESIDENTS COMPANY LIMITED | 20. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STEELACE LIMITED | 20. Juni 1991 | 26. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EOC UK LIMITED | 20. Juni 1991 | 28. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LL SHELL LIMITED | 19. Juni 1991 | 19. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VICTOR CNC (UK) LIMITED | 19. Juni 1991 | 01. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WESTERN ENVIRONMENTAL LIMITED | 17. Juni 1991 | 11. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SUTTON FINANCIAL CONSULTANTS LTD. | 17. Juni 1991 | 09. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONNOR LIMITED | 14. Juni 1991 | 14. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CASTLE MILL PRINT LIMITED | 12. Juni 1991 | 12. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WILBRAHAM MANAGEMENT LIMITED | 05. Juni 1991 | 18. Nov. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NELSON BEEF COMPANY LIMITED | 05. Juni 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RISHTON BEEF COMPANY LIMITED | 04. Juni 1991 | 18. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0