BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 135
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNSTERS FARM (HOLDINGS) LIMITED | 10. Juli 1991 | 10. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRIDGE CAR COMPANY LIMITED | 05. Juli 1991 | 05. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LAM-FAB LIMITED | 05. Juli 1991 | 18. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MELLOR BEEF COMPANY LIMITED | 05. Juli 1991 | 26. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LONGRIDGE BEEF COMPANY LIMITED | 03. Juli 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FINCH ASSOCIATES LIMITED | 28. Juni 1991 | 31. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A T MOUNTFORD LIMITED | 28. Juni 1991 | 20. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INNERCODE LIMITED | 27. Juni 1991 | 16. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LINKDEAL LIMITED | 27. Juni 1991 | 09. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| UK RIGGING LTD | 27. Juni 1991 | 12. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SIMPLER SHOPPING LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHESTER INTERNATIONAL LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DEE - SCAN LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MDF DESIGN LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DEALERCAST LIMITED | 24. Juni 1991 | 20. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STAFFORD GLAZING SERVICES LIMITED | 24. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TOTTLEWORTH BEEF COMPANY LIMITED | 24. Juni 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VENTUREPULSE LIMITED | 24. Juni 1991 | 15. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SPRINTDELIVER LIMITED | 24. Juni 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CAN DO BUSINESS SERVICES LIMITED | 21. Juni 1991 | 21. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| QPC LIMITED | 20. Juni 1991 | 30. Jan. 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A.N. FASHIONS LIMITED | 20. Juni 1991 | 20. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| READYEARN LIMITED | 20. Juni 1991 | 03. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE GRANARIES RESIDENTS COMPANY LIMITED | 20. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STEELACE LIMITED | 20. Juni 1991 | 26. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EOC UK LIMITED | 20. Juni 1991 | 28. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LL SHELL LIMITED | 19. Juni 1991 | 19. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VICTOR CNC (UK) LIMITED | 19. Juni 1991 | 01. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WESTERN ENVIRONMENTAL LIMITED | 17. Juni 1991 | 11. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SUTTON FINANCIAL CONSULTANTS LTD. | 17. Juni 1991 | 09. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CONNOR LIMITED | 14. Juni 1991 | 14. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CASTLE MILL PRINT LIMITED | 12. Juni 1991 | 12. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WILBRAHAM MANAGEMENT LIMITED | 05. Juni 1991 | 18. Nov. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NELSON BEEF COMPANY LIMITED | 05. Juni 1991 | 23. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RISHTON BEEF COMPANY LIMITED | 04. Juni 1991 | 18. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0