BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 131
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
TAYLORS LEGAL SERVICES LIMITED | 04. Nov. 1991 | 17. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TIE-WISE (UK) LIMITED | 17. Dez. 1991 | 17. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MEGANET LIMITED | 22. Nov. 1991 | 17. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MARINE COURT (FRINTON) LIMITED | 13. Dez. 1991 | 13. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WARDERVILLE LIMITED | 13. Dez. 1991 | 13. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAMEL PROPERTY SERVICES LIMITED | 15. Nov. 1991 | 13. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ASPREY HARRIS INSURANCE CONSULTANTS LIMITED | 11. Dez. 1991 | 11. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INTEGRATED DESIGN ENGINEERING ASSOCIATES LTD | 11. Dez. 1991 | 11. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED | 11. Dez. 1991 | 11. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PAUL FITTON ACCOUNTANCY LTD | 11. Dez. 1991 | 11. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
G. W. INSTALL CARPET LIMITED | 11. Dez. 1991 | 11. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
P. JACKSON (PLYWOOD) LIMITED | 06. Dez. 1991 | 10. Dez. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AUTOLODGE HOTEL LIMITED | 09. Dez. 1991 | 09. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EMMA SMYTH LIMITED | 02. Dez. 1991 | 09. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE BROADCASTING COMPANY LTD. | 09. Dez. 1991 | 09. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOWNSEND MCCORMACK LTD. | 06. Dez. 1991 | 06. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FREEDISC LIMITED | 02. Dez. 1991 | 05. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POWERTHEME LIMITED | 02. Dez. 1991 | 04. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VOLUMERELAY LIMITED | 06. Nov. 1991 | 04. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONTACTFORCE LIMITED | 20. Nov. 1991 | 03. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOUNTAIN ASH LIMITED | 21. Okt. 1991 | 03. Dez. 1991 | In Verwaltung | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GLOSSOP NORTH END ASSOCIATION FOOTBALL CLUB LIMITED | 02. Dez. 1991 | 02. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BONDCARE MANAGEMENT (1991) LIMITED | 02. Dez. 1991 | 02. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AUTODATA COMPUTER SERVICES LIMITED | 02. Dez. 1991 | 02. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHEMIPHASE LIMITED | 02. Dez. 1991 | 02. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
IFA NETWORK (SERVICES) LIMITED | 02. Dez. 1991 | 02. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CUSTOMFORM LIMITED | 15. Nov. 1991 | 02. Dez. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LLOYDS CARAVAN SALES CO. LIMITED | 28. Nov. 1991 | 28. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DUGDALE MERCHANTS LIMITED | 11. Nov. 1991 | 28. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANTARES IT SERVICES LIMITED | 15. Nov. 1991 | 28. Nov. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
QUI LIMITED | 13. Nov. 1991 | 28. Nov. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
K.R.H. PROPERTIES LIMITED | 15. Nov. 1991 | 27. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
F.T.F. LIMITED | 26. Nov. 1991 | 26. Nov. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE MEAD RESIDENTS LIMITED | 26. Nov. 1991 | 26. Nov. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BENJAMIN KAY WHOLESALE LIMITED | 25. Nov. 1991 | 25. Nov. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0