BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 136
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
T.C. MEATS LIMITED | 15. Mai 1991 | 09. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SUTTON FINANCIAL CONSULTANTS LTD. | 17. Juni 1991 | 09. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRIDGE CAR COMPANY LIMITED | 05. Juli 1991 | 05. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
READYEARN LIMITED | 20. Juni 1991 | 03. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GRACO GROUP LIMITED | 28. Mai 1991 | 01. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J & B PROMOTIONS DISTRIBUTION LIMITED | 03. Juni 1991 | 30. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEE - SCAN LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J.S.M. FINANCE LIMITED | 21. Jan. 1991 | 27. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHESTER INTERNATIONAL LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STRATEGY THREE LIMITED | 10. Apr. 1991 | 27. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SIMPLER SHOPPING LIMITED | 27. Juni 1991 | 27. Juni 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE GRANARIES RESIDENTS COMPANY LIMITED | 20. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STAFFORD GLAZING SERVICES LIMITED | 24. Juni 1991 | 24. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAN DO BUSINESS SERVICES LIMITED | 21. Juni 1991 | 21. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.N. FASHIONS LIMITED | 20. Juni 1991 | 20. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIONSTRIDE LIMITED | 22. Mai 1991 | 20. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LL SHELL LIMITED | 19. Juni 1991 | 19. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HUNCOAT BEEF COMPANY LIMITED | 22. Mai 1991 | 18. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RISHTON BEEF COMPANY LIMITED | 04. Juni 1991 | 18. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FENCE BEEF COMPANY LIMITED | 04. Juni 1991 | 18. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GISBURN BEEF COMPANY LIMITED | 22. Mai 1991 | 18. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PRIMEPURPOSE LIMITED | 04. Juni 1991 | 18. Juni 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONNOR LIMITED | 14. Juni 1991 | 14. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SHAKO SITE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 16. Mai 1991 | 14. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CASTLE MILL PRINT LIMITED | 12. Juni 1991 | 12. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GAMAR TELECOMMUNICATIONS (UK) LIMITED | 15. Mai 1991 | 11. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
F. R. ELSWOOD LIMITED | 04. Juni 1991 | 04. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRETBY ANALYTICAL CONSULTANTS LIMITED | 04. Juni 1991 | 04. Juni 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TITAN METAL FABRICATIONS LIMITED | 03. Juni 1991 | 03. Juni 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INSURANCE AND LEGAL SERVICES LIMITED | 17. Mai 1991 | 30. Mai 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DIGBITS LIMITED | 29. Mai 1991 | 29. Mai 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
U.K. HEAT TECHNOLOGY LIMITED | 28. Mai 1991 | 28. Mai 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CROSSLEY CARPETS LIMITED | 28. Mai 1991 | 28. Mai 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOGETHER PERSONAL FINANCE LIMITED | 22. Mai 1991 | 22. Mai 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE PRINTED WORD BUSINESS AND PROMOTIONAL PRINT LIMITED | 21. Mai 1991 | 21. Mai 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0