BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 17
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAUNIT LIMITED | 15. Juni 1998 | 25. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HANNAH MARTIN HOLDINGS LIMITED | 15. Juni 1998 | 15. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BIOANALYTICAL SYSTEMS LIMITED | 15. Juni 1998 | 26. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| M. CUNNINGTON UPHOLSTERY CENTRE LIMITED | 15. Juni 1998 | 16. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RANDOMVISION LIMITED | 15. Juni 1998 | 22. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COVERTONE LIMITED | 15. Juni 1998 | 14. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ETERNA EUROPE LIMITED | 15. Juni 1998 | 18. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MARK BURR ASSOCIATES LIMITED | 15. Juni 1998 | 19. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BASEUNIT LIMITED | 15. Juni 1998 | 01. Sept. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRADEFUND INVESTMENTS LIMITED | 15. Juni 1998 | 06. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SELECTACTION LIMITED | 15. Juni 1998 | 13. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MODERN CYBERNETICS LIMITED | 15. Juni 1998 | 30. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MARKETBALANCE LIMITED | 15. Juni 1998 | 23. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BROMPTON BUILDING COMPANY LIMITED | 12. Juni 1998 | 12. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MCCLELLAN INDUSTRIAL SERVICES LIMITED | 12. Juni 1998 | 12. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FLINTSHIRE INDUSTRIAL TRAINING LIMITED | 11. Juni 1998 | 11. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MATCH-IT LIMITED | 11. Juni 1998 | 11. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RAINER UK LIMITED | 11. Juni 1998 | 11. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SOUTH WEST RECRUITMENT LIMITED | 11. Juni 1998 | 11. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| M60 LIMITED | 09. Juni 1998 | 09. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALOE FLATS LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MIART TECHNOLOGY LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FASTPARTS MOTOR FACTORS LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRADTECH (PRESTON) LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOHN FLETCHER (KNUTSFORD) LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MERLIN E.D.M. LIMITED | 08. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NEWMINSTER PROPERTIES LIMITED | 05. Juni 1998 | 05. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COTTON CONSULTANCY LIMITED | 05. Juni 1998 | 05. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COMPLETE COMPLIANCE LIMITED | 05. Juni 1998 | 05. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STRAIGHT TALK PRODUCTION LIMITED | 04. Juni 1998 | 04. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DATABASE WORKSHOP (UK) LIMITED | 04. Juni 1998 | 04. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CAMERON CHASE LIMITED | 04. Juni 1998 | 04. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE TIDALWAVE GROUP LIMITED | 04. Juni 1998 | 04. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LEXON GIFTS LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE EPIPHANY AGENCY LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0