BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 133
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
ROWAN TECHNOLOGIES LIMITED | 11. Okt. 1991 | 11. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MIKE WALSH (REFRIGERATION) LIMITED | 11. Okt. 1991 | 11. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRIAN C. CORCORAN LIMITED | 30. Sept. 1991 | 08. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CROSBY CAPITAL PARTNERS LIMITED | 07. Okt. 1991 | 07. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENVIRONMENTAL EVALUATION LIMITED | 24. Sept. 1991 | 04. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BENCH GLOBAL LIMITED | 29. Aug. 1991 | 04. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DESKTOP PROJECTS LIMITED | 03. Okt. 1991 | 03. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DAVID WALTER (HOLDINGS) LIMITED | 03. Okt. 1991 | 03. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PICTUREBUILD LIMITED | 08. Aug. 1991 | 01. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TRAILBUILD LIMITED | 31. Juli 1991 | 30. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CABLE AND GENERAL ELECTRICAL TESTING SERVICES LIMITED | 27. Sept. 1991 | 27. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SATVISION PUBLIC LIMITED COMPANY | 27. Sept. 1991 | 27. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INITIALCHOICE LIMITED | 18. Sept. 1991 | 26. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NEWTON SCREEN PRINT LIMITED | 12. Sept. 1991 | 26. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
OPENFEATURE LIMITED | 21. Mai 1991 | 26. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BENNETT BROOKS & CO LIMITED | 25. Sept. 1991 | 25. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EAGLE PARADE (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | 24. Sept. 1991 | 24. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE GRAPEVINE CLUB LIMITED | 24. Sept. 1991 | 24. Sept. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HARLSTONE TRANSPORT LIMITED | 23. Sept. 1991 | 23. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GPC COMPUTER SOFTWARE LIMITED | 11. Juli 1991 | 23. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A T MOUNTFORD LIMITED | 28. Juni 1991 | 20. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHRISTOPHER JACKSON LIMITED | 19. Sept. 1991 | 19. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
UNIVERSAL INTERNATIONAL AIRWAYS LIMITED | 19. Sept. 1991 | 19. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FORREST COURT MANAGEMENT CO. LIMITED | 17. Sept. 1991 | 17. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VALUE REALISATIONS LIMITED | 16. Sept. 1991 | 16. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HALON AND REFRIGERANT SERVICES LIMITED | 12. Sept. 1991 | 12. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KUK LIMITED | 12. Sept. 1991 | 12. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
COPYSCOPE LIMITED | 29. Aug. 1991 | 10. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DELTA TELECOM SOUND AND SECURITY LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE COSMETIC SURGERY CENTRE LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
G.M.F. PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NW JAMES ASSOCIATES LIMITED | 23. Aug. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RESTORE COMPUTER SERVICES LIMITED | 06. Sept. 1991 | 06. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONTRAFLOR (CONTRACT FLOORING SERVICES) LIMITED. | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CARPET TRADE SUPPLIES (MACCLESFIELD) LIMITED | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0