BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 133
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON SCREEN PRINT LIMITED | 12. Sept. 1991 | 26. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KUK LIMITED | 12. Sept. 1991 | 12. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE COSMETIC SURGERY CENTRE LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| G.M.F. PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DELTA TELECOM SOUND AND SECURITY LIMITED | 09. Sept. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RESTORE COMPUTER SERVICES LIMITED | 06. Sept. 1991 | 06. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CONTRAFLOR (CONTRACT FLOORING SERVICES) LIMITED. | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CARPET TRADE SUPPLIES (MACCLESFIELD) LIMITED | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KORE TECHNOLOGY LIMITED | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ROBERT LLOYD ASSOCIATES LIMITED | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| I.W.CHUWIN (UK) LIMITED | 04. Sept. 1991 | 04. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CROWN METAL FABRICATIONS LIMITED | 03. Sept. 1991 | 03. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EURO CLOTHING DESIGN LIMITED | 02. Sept. 1991 | 02. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JB FABRICATIONS LIMITED | 02. Sept. 1991 | 29. Okt. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BENCH GLOBAL LIMITED | 29. Aug. 1991 | 04. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COPYSCOPE LIMITED | 29. Aug. 1991 | 10. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| UNO (SWINTON) LTD | 29. Aug. 1991 | 29. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SKILLSET COMPUTER SERVICES LIMITED | 29. Aug. 1991 | 29. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| K & M HULME (PROPERTIES) LIMITED | 27. Aug. 1991 | 27. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CENTRAL MEDICAL SUPPLIES LIMITED | 27. Aug. 1991 | 27. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GEMINI DISTRIBUTION (U.K.) LIMITED | 27. Aug. 1991 | 27. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NW JAMES ASSOCIATES LIMITED | 23. Aug. 1991 | 09. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| W.I.N. INDUSTRIAL NETWORKS (EUROPE) LIMITED | 23. Aug. 1991 | 23. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AGOG LIMITED | 21. Aug. 1991 | 21. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BASIC SOFTWARE SERVICES LIMITED | 21. Aug. 1991 | 21. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ITEMDESIGN LIMITED | 21. Aug. 1991 | 02. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| OPTIMIST INVESTMENTS LIMITED | 21. Aug. 1991 | 21. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRIPLE C HEALTHCARE LIMITED | 20. Aug. 1991 | 20. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COMFREIGHT LIMITED | 19. Aug. 1991 | 19. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EDWARDS OF SALE LIMITED | 19. Aug. 1991 | 27. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| S.E.C. SYSTEMS LIMITED | 16. Aug. 1991 | 02. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EVENCHARGE LIMITED | 13. Aug. 1991 | 13. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PHILLIPS BOOTH CONSTRUCTION LIMITED | 13. Aug. 1991 | 13. Aug. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOINTLINK LIMITED | 13. Aug. 1991 | 29. Aug. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| IPTC LIMITED | 13. Aug. 1991 | 02. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0