BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 59
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLLY DRAGON FOODS LIMITED | 13. Nov. 1996 | 07. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ERNEST J. OLDFIELD & DAUGHTER LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PERFORMANCE TICKET PRINTERS LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KINETIC PROCESS MANAGEMENT LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BENCHMARK INTERIORS LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| R H P HYDRAULIC SERVICES LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CRAIGROCK CONSULTING LIMITED | 12. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| U.K. FIRE SECURITIES LIMITED | 08. Nov. 1996 | 11. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CORVUS LIMITED | 08. Nov. 1996 | 11. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LISCOT LIMITED | 08. Nov. 1996 | 11. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PRIMESCORE LIMITED | 07. Nov. 1996 | 13. Dez. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VISIONLIGHT LIMITED | 07. Nov. 1996 | 20. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KEN THOMAS LOGISTICS LIMITED | 07. Nov. 1996 | 08. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INSPIRATIONS WHOLESALE LIMITED | 07. Nov. 1996 | 08. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| OBJECTSCORE LIMITED | 07. Nov. 1996 | 27. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CAMILLA CONSULTING LIMITED | 07. Nov. 1996 | 08. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JONES RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED | 07. Nov. 1996 | 31. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VIOLET HILL STUDIOS LIMITED | 07. Nov. 1996 | 08. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MAAN ENGINEERING LIMITED | 06. Nov. 1996 | 07. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INLAND & INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES LIMITED | 06. Nov. 1996 | 07. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| B.W. AYLESBURY LIMITED | 06. Nov. 1996 | 03. März 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DMC PUBLISHING LIMITED | 06. Nov. 1996 | 22. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ATOMEDIA LIMITED | 06. Nov. 1996 | 07. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INITIALACCESS LIMITED | 06. Nov. 1996 | 20. Dez. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COOMBES WELDING LTD | 05. Nov. 1996 | 06. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NATIONWIDE PRODUCE HOLDINGS PLC | 05. Nov. 1996 | 06. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| G M W PRECISION POLISHING LIMITED | 05. Nov. 1996 | 06. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHORLEY COACHCRAFT (LANCS) LIMITED | 05. Nov. 1996 | 06. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MCLUCKIE PROJECTS LIMITED | 04. Nov. 1996 | 26. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TILBURY AGGREGATES LIMITED | 04. Nov. 1996 | 28. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SOLIDMETHOD LIMITED | 01. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| QUAY COMPUTING LIMITED | 01. Nov. 1996 | 04. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TECHIE LIMITED | 31. Okt. 1996 | 01. Nov. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| OPTIMUM VEHICLE CONTRACTS LIMITED | 31. Okt. 1996 | 01. Nov. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WESTWOOD CONTRACTS (SWINDON) LIMITED | 31. Okt. 1996 | 07. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0