BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 56
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
NETWORK ASSET FINANCE LIMITED | 22. Jan. 1997 | 22. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C M TAX CONSULTANTS LIMITED | 21. Jan. 1997 | 22. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED | 21. Jan. 1997 | 28. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PUBLICLINK LIMITED | 21. Jan. 1997 | 13. März 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FAIRWAY (GOLF SHOPS) LIMITED | 21. Jan. 1997 | 22. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MILL PRINTERS LIMITED | 21. Jan. 1997 | 29. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PHOENIX COMPUTERS INTERNATIONAL LIMITED | 21. Jan. 1997 | 22. Jan. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PARTNERSHIP MEDIA GROUP LIMITED | 20. Jan. 1997 | 21. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
M AND C WILKINSON LTD | 20. Jan. 1997 | 21. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FINANCIAL SECURITY LIMITED | 20. Jan. 1997 | 20. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ARDMORE RESOURCES LIMITED | 20. Jan. 1997 | 23. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
COMMERCIAL ACQUISITIONS LIMITED | 20. Jan. 1997 | 20. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NEOVENATOR LTD | 16. Jan. 1997 | 24. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MASH (UK) LIMITED | 16. Jan. 1997 | 17. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ST. HELEN'S PLACE INVESTMENTS LIMITED | 16. Jan. 1997 | 24. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PHAROS 8 LIMITED | 16. Jan. 1997 | 06. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HALLMARK ANTIQUE FAIRS LIMITED | 16. Jan. 1997 | 17. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENGLISH COUNTRY MANORS LIMITED | 16. Jan. 1997 | 17. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CARRS OF SHEFFIELD LIMITED | 16. Jan. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
OAKFIELD P.M. LIMITED | 14. Jan. 1997 | 15. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INSTRUMENTATION SUPPORT SERVICES LIMITED | 14. Jan. 1997 | 15. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ORCHARD BUSINESS SYSTEMS LIMITED | 14. Jan. 1997 | 15. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C S BLASTING LIMITED | 14. Jan. 1997 | 15. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INITIAL TEXTILE SERVICES LIMITED | 10. Jan. 1997 | 13. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FIRST INSPIRED LTD | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ROCHPLANT LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STANGLE PREPARATION LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NORCOMM (UK) LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AVOMECH LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TUSSIE MUSSIE LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CASTLE CONSTRUCTION (NORTH EAST) LIMITED | 02. Jan. 1997 | 03. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CREATE ! FORM INTERNATIONAL LIMITED | 02. Jan. 1997 | 07. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BOOKER TIMBER LIMITED | 30. Dez. 1996 | 02. Jan. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POINT CONTROL PRINT FINISHING LIMITED | 24. Dez. 1996 | 02. Jan. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FIX UP PRODUCTIONS LIMITED | 23. Dez. 1996 | 24. Dez. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0