BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 85
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
MCGARRIE TRANSPORT LIMITED | 06. Juli 1995 | 07. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROTOTYPE MOULDINGS AND DEVELOPMENTS LIMITED | 06. Juli 1995 | 07. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROFINANCE PARTNERS LIMITED | 06. Juli 1995 | 07. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LUNATECH LIMITED | 06. Juli 1995 | 07. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACE FIRE ALARMS & SECURITY LIMITED | 05. Juli 1995 | 06. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FKB MECHANICAL LIMITED | 05. Juli 1995 | 06. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HARRISON'S (THE WINDOW AND CONSERVATORY COMPANY) LIMITED | 05. Juli 1995 | 06. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MORLAND SERVICES LIMITED | 05. Juli 1995 | 06. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENTREPRENEUR BUSINESS PUBLISHING LIMITED | 05. Juli 1995 | 06. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TECSEAL LIMITED | 16. März 1995 | 06. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HYDE PARK PUBLIC RELATIONS LIMITED | 05. Juli 1995 | 05. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
APPLEDORE PACKAGING LIMITED | 03. Juli 1995 | 04. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADVISORYPE LIMITED | 30. Juni 1995 | 03. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANTHONY BOARDMAN DESIGNS LIMITED | 30. Juni 1995 | 03. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHURCHILL SERVICES LIMITED | 30. Juni 1995 | 03. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REDROX QUARRY PRODUCTS LIMITED | 03. März 1995 | 03. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MANAGEMENT TOOLS LIMITED | 30. Juni 1995 | 03. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TACTICAL TAX PLANNING LIMITED | 30. Juni 1995 | 03. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SYSTEMCORE LIMITED | 15. Juni 1995 | 30. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
S & H COMPUTER CONSULTANTS LIMITED | 21. März 1995 | 30. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
QUALITYCOURSE LIMITED | 12. Mai 1995 | 30. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHECK COMMUNICATIONS LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STOW (UK) LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ESUS FORESTRY AND WOODLANDS LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HOWARTH COMMUNICATIONS LIMITED | 21. März 1995 | 29. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STABLE MEWS (BEAUMARIS) MANAGEMENT LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
OPTIKOM LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HEALTHCARE NORTH EAST LIMITED | 28. Juni 1995 | 29. Juni 1995 | Freiwillige Vereinbarung | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AMICI TRADING LIMITED | 26. Juni 1995 | 27. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KEVIN HOLLIDAY LIMITED | 23. Juni 1995 | 26. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
IPL FLUID POWER LIMITED | 23. Juni 1995 | 26. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ERNEST WILSONS & CO LIMITED | 21. Juni 1995 | 22. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
IMPACT C & T LIMITED | 21. Juni 1995 | 22. Juni 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GREENASH SYSTEMS LIMITED | 20. Juni 1995 | 21. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SHAKTI LIMITED | 20. Juni 1995 | 21. Juni 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0