BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 129
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPT INTERIORS NESTON LIMITED | 04. Feb. 1992 | 04. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DIAMONDFUTURE LIMITED | 04. Feb. 1992 | 07. Feb. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ARM BIOSOLIDS LTD | 03. Feb. 1992 | 03. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PILATES NORTH WEST LIMITED | 03. Feb. 1992 | 03. Feb. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A & Q PARTNERSHIP (LONDON) LIMITED | 03. Feb. 1992 | 17. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NATIONWIDE FRANKING SENSE LIMITED | 31. Jan. 1992 | 31. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| R J LEISURE LIMITED | 28. Jan. 1992 | 28. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EQUALUNIT LIMITED | 28. Jan. 1992 | 01. Apr. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GPC74 LIMITED | 28. Jan. 1992 | 28. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LABEL HQ LIMITED | 28. Jan. 1992 | 28. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| 4TH DIMENSION RENOVATIONS LIMITED | 27. Jan. 1992 | 31. März 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HYPROSTEPS LIMITED | 27. Jan. 1992 | 27. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SUNNYVILLE CLOTHING LIMITED | 27. Jan. 1992 | 27. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STYLETITLE LIMITED | 20. Jan. 1992 | 30. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| IRLAM COMMERCIALS LIMITED | 20. Jan. 1992 | 20. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DEAN MILL LIMITED | 20. Jan. 1992 | 28. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CCRR LIMITED | 16. Jan. 1992 | 16. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BUSINESS CREDIT RATINGS LIMITED | 16. Jan. 1992 | 05. Feb. 1992 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| E A P PROPERTY SERVICES LIMITED | 16. Jan. 1992 | 16. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SILKOM (VOICE AND DATA) LIMITED | 16. Jan. 1992 | 16. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TOUCHSTRIDE LIMITED | 15. Jan. 1992 | 30. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHALLENGE AVIATION SERVICES LIMITED | 14. Jan. 1992 | 14. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AARON CHEMICALS LIMITED | 13. Jan. 1992 | 13. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JIM BARLOW STATIONERS LIMITED | 13. Jan. 1992 | 14. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CASTLETON TEXTILES LIMITED | 13. Jan. 1992 | 13. Jan. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STOCKPORT CENTRE TAXIS LIMITED | 13. Jan. 1992 | 13. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| E & P COATINGS LIMITED | 10. Jan. 1992 | 13. Apr. 1992 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VALIDASPECT LIMITED | 10. Jan. 1992 | 06. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GRAPHISIGN UK LIMITED | 06. Jan. 1992 | 09. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EQUALRESPONSE LIMITED | 31. Dez. 1991 | 12. Feb. 1992 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FORTUNELODGE LIMITED | 31. Dez. 1991 | 31. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STRIKETRIAL LIMITED | 23. Dez. 1991 | 10. Jan. 1992 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRIDENT STEEL (REINFORCEMENTS) LIMITED | 20. Dez. 1991 | 20. Dez. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ACACIA RESORTS LTD. | 20. Dez. 1991 | 20. Dez. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TURTON-TYZACK LIMITED | 19. Dez. 1991 | 31. Jan. 1992 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0