BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 134
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
KITCHEN & BEDROOM CONSULTANTS (KBC) LIMITED | 13. Aug. 1991 | 29. Aug. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PINK PIG INTERNATIONAL LTD | 09. Aug. 1991 | 09. Aug. 1991 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PICTUREBUILD LIMITED | 08. Aug. 1991 | 01. Okt. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ENVIRON WATER TECHNOLOGY LIMITED | 08. Aug. 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TECHNICAL NETWORK INITIATIVE LIMITED | 08. Aug. 1991 | 27. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOMERSET CARAVAN SERVICES LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE HERITAGE (LYTHAM) LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REGENCY TRADE FINANCE LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BTS (CONGLETON) LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAFE ESPRESS (E.C.) LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C P MANAGEMENT COMPANY II LIMITED | 02. Aug. 1991 | 02. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TRAILBUILD LIMITED | 31. Juli 1991 | 30. Sept. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAUNDRY & WORKWEAR SERVICES LIMITED | 31. Juli 1991 | 31. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
IMMANUEL BEEF COMPANY LIMITED | 31. Juli 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLENSTON LIMITED | 29. Juli 1991 | 29. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MBC EDUCATIONAL SUPPLIES LIMITED | 29. Juli 1991 | 29. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GRANART LIMITED | 29. Juli 1991 | 29. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VALUE VIDEOS LIMITED | 26. Juli 1991 | 26. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PRIMETREND LIMITED | 26. Juli 1991 | 19. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ASBURY ASSOCIATES. | 25. Juli 1991 | 25. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GMGRM 1007 LIMITED | 22. Juli 1991 | 09. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROFAL LIMITED | 22. Juli 1991 | 22. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D.R. MORRIS LIMITED | 22. Juli 1991 | 22. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BANNER VAN HIRE LIMITED | 22. Juli 1991 | 22. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ELITE CRETE LIMITED | 22. Juli 1991 | 22. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAYCO LIMITED | 18. Juli 1991 | 18. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TREEWOOD TIMBER LIMITED | 18. Juli 1991 | 18. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DANIEL LODGE DEVELOPMENTS LIMITED | 18. Juli 1991 | 18. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLEAN MACHINE RESIDENTIAL LIMITED | 17. Juli 1991 | 17. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MENAI BRIDGE WATERFRONT PUBLIC LIMITED COMPANY | 16. Juli 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INTEC SYSTEMS (BLACKBURN) LIMITED | 16. Juli 1991 | 22. Nov. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SALCOMBE BEEF CO LTD | 12. Juli 1991 | 08. Aug. 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FLIGHT DYNAMICS LIMITED | 12. Juli 1991 | 12. Juli 1991 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NORTHERN HEIGHTS LIMITED | 12. Juli 1991 | 12. Juli 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GPC COMPUTER SOFTWARE LIMITED | 11. Juli 1991 | 23. Sept. 1991 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0