BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 84
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
CLIVE CHRISTIAN WEYBRIDGE LIMITED | 18. Apr. 1995 | 28. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MACKENZIES LIMITED | 27. Juli 1995 | 28. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J. MCEVILLY LIMITED | 25. Juli 1995 | 26. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
URMSTON SERVICE STATION LIMITED | 25. Juli 1995 | 26. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WILLIAMS & MORROW LIMITED | 25. Juli 1995 | 26. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GOLDENZONE LIMITED | 16. Juni 1995 | 26. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ONDEMAND LIMITED | 25. Juli 1995 | 26. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADMIN 12345 LIMITED | 24. Juli 1995 | 25. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FOLLOW SUIT LIMITED | 24. Juli 1995 | 25. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LYNCH KNOLL WIND PARK LIMITED | 20. Juli 1995 | 21. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
L/C EXPEDITE - LETTER OF CREDIT MANAGEMENT FOR EXPORTERS LIMITED | 20. Juli 1995 | 21. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FEATURECRAFT LIMITED | 13. Juni 1995 | 21. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
COMMSEC MONITORING COMPANY LIMITED | 19. Juli 1995 | 20. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHERRY TREE PROPERTIES LIMITED | 18. Juli 1995 | 19. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MODERN VINTAGE WINES LTD | 20. Juni 1995 | 19. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEVON 4 X 4 CENTRE LIMITED | 18. Juli 1995 | 18. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VIRTIX LIMITED | 14. Juli 1995 | 17. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAGO ESTATES LIMITED | 22. Mai 1995 | 17. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
W.D.F. PROMOTIONS LIMITED | 14. Juli 1995 | 17. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DONALDSON EDWARDS PARTNERSHIP LIMITED | 14. Juli 1995 | 17. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
L.P. GRIFFITHS LIMITED | 13. Juli 1995 | 14. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
U.P.C. LIMITED | 13. Juli 1995 | 14. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R. AND R. ENTERPRISES LIMITED | 13. Juli 1995 | 14. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AUTOMAT DISTRIBUTORS LIMITED | 12. Juli 1995 | 13. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TAN (UK) LIMITED | 12. Juli 1995 | 13. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HUMPHREY CONTRACTING LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TEST VALLEY GLASS AND WINDOW COMPANY LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INTERNATIONAL MANAGEMENT & AGENCY LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FAMILY TREE REPRODUCTIONS LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ERIC SHAKESPEARE LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HOME LANGUAGE LEARNING LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GILBERT BROWN & SON (TRANSPORT) LIMITED | 10. Juli 1995 | 11. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
B V M SERVICES LIMITED | 10. Juli 1995 | 11. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MAYOS LIMITED | 10. Juli 1995 | 11. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BERKELEY MANAGEMENT & FINANCIAL LIMITED | 10. Juli 1995 | 11. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0