BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 93
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
DYNAMIC PRODUCTS LIMITED | 21. Nov. 1994 | 30. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BLACKSTAR GM LTD | 16. Nov. 1994 | 30. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PARKHALL ESTATES (MANAGEMENT) LIMITED | 27. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LAKES CONSULTANTS LIMITED | 25. Jan. 1995 | 26. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FOTHERGILL BIOTECH LIMITED | 24. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MCENTEGART SOFTWARE LIMITED | 24. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.F.A. BENCHMARK LIMITED | 25. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED | 24. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VERDE SPORTS (CRICKET) LIMITED | 24. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LIVING PICTURES LIMITED | 28. Nov. 1994 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SYNCREON AUTOMOTIVE (UK) LTD. | 23. Jan. 1995 | 24. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
QUINN INTERIORS LIMITED | 14. Nov. 1994 | 24. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CROSSLEY COACHCRAFT LIMITED | 24. Okt. 1994 | 24. Jan. 1995 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MARTINAIR LIMITED | 20. Jan. 1995 | 23. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KEVIN WALKER (CONSULTANTS) LTD. | 20. Jan. 1995 | 23. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
OMEGA GOLD LIMITED | 13. Jan. 1995 | 23. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
COMPURENT LIMITED | 18. Jan. 1995 | 18. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BODYSHOP TECHNICAL SERVICES LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
G.C.S. PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HABCO PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WALMSLEY & CO ACCOUNTANTS LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PETER WORTHINGTON ROOFING SLATER & TILER LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GEO. GRACE & CO. LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D A ASSOCIATES LIMITED | 16. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GENERALPOINT LIMITED | 03. Jan. 1995 | 16. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NATIONWIDE FLEET INSTALLATIONS LTD | 03. Jan. 1995 | 13. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STORMPROOFINGS LIMITED | 01. Dez. 1994 | 11. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R.D. PRECISION LIMITED | 10. Jan. 1995 | 11. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R.D. HOLDINGS LIMITED | 09. Jan. 1995 | 09. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SMITH HOLT HOLDINGS PLC | 09. Jan. 1995 | 09. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TIME COMPUTERS (EUROPE) LIMITED | 18. März 1994 | 09. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J.H. HASLAM (PRESTON) LIMITED | 05. Jan. 1995 | 06. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BEMBRIDGE COMMUNICATIONS LIMITED | 09. Dez. 1994 | 04. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE MEDICINE SHOP LIMITED | 03. Jan. 1995 | 04. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DIRECT FOOD INGREDIENTS LIMITED | 23. Dez. 1994 | 03. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0