BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 18
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
TIDALWAVE INTERNATIONAL LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LEXON (GB) LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LEECO BUILDING SERVICES LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JOINT LEARNING PARTNERSHIP LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KNOWLEDGE GARDEN CONSULTING LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TWISTER INTERACTIVE LIMITED | 03. Juni 1998 | 03. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ARTISAN FABRICS LIMITED | 02. Juni 1998 | 02. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KASHMIR FORUM | 02. Juni 1998 | 02. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J. BROOKS DESIGNS LIMITED | 02. Juni 1998 | 02. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANTISOCIAL SOFTWARE LIMITED | 02. Juni 1998 | 02. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WRIGHT WRIGHT WRIGHT LIMITED | 02. Juni 1998 | 02. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
W H SINGLETON LIMITED | 29. Mai 1998 | 29. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALAN J BRADLEY & SONS LIMITED | 29. Mai 1998 | 29. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BELL CHOICE LIMITED | 29. Mai 1998 | 18. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MULTI SAVE WAREHOUSE LIMITED | 29. Mai 1998 | 29. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
P.B.SOLUTIONS LIMITED | 29. Mai 1998 | 29. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALDEN DEVELOPMENTS (NW) LIMITED | 29. Mai 1998 | 15. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MOSSWOOD PROPERTIES LIMITED | 29. Mai 1998 | 19. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WARRINGTON BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED | 29. Mai 1998 | 11. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PERCALF LIMITED | 29. Mai 1998 | 29. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TRADEACTION LIMITED | 29. Mai 1998 | 11. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PARAMOUNT PRINT GROUP LIMITED | 29. Mai 1998 | 07. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SONICVISION LIMITED | 29. Mai 1998 | 10. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLIMATE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | 28. Mai 1998 | 28. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STOMPERS FOOTWEAR LIMITED | 28. Mai 1998 | 28. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SPECTRAL IMAGE LIMITED | 28. Mai 1998 | 28. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BLACK OPAL LIMITED | 28. Mai 1998 | 28. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LIVERPOOL AVIATION SERVICES LIMITED | 27. Mai 1998 | 27. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C.B.S. BUILDING AND LANDSCAPING LIMITED | 27. Mai 1998 | 27. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SYSMEDIA LIMITED | 27. Mai 1998 | 27. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R & B SERVICES (OFFICE SUPPORT) LIMITED | 27. Mai 1998 | 27. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
APPLIANCE SERVICES (A-U-L) LIMITED | 21. Mai 1998 | 21. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLARENDON ACCOUNTING SOLUTIONS LIMITED | 21. Mai 1998 | 21. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BONTHORPE CONSTRUCTION LIMITED | 21. Mai 1998 | 21. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOURISM DESTINATION SERVICES LIMITED | 21. Mai 1998 | 21. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0