BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 112
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
SAMBA SPORTS LIMITED | 28. Juni 1993 | 28. Juni 1993 | Aktiv | Bevollm ächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CATWALK LIMITED | 28. Juni 1993 | 28. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DYNAMIC PUMP SERVICES LIMITED | 25. Juni 1993 | 25. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TENTERDEN RAILWAY EQUIPMENT AND TRACTION COMPANY LIMITED | 26. Mai 1993 | 25. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EXOL LUBRICANTS (ROTHERHAM) LIMITED | 13. Apr. 1993 | 24. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NATURALPOINT LIMITED | 18. Juni 1993 | 24. Juni 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MARTIN FLANNERY LIMITED | 23. Juni 1993 | 23. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE CLUB SECURITY COMPANY LIMITED | 23. Juni 1993 | 23. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALLIED STANDARD FINANCIAL SERVICES LIMITED | 23. Juni 1993 | 23. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
G TEK SYSTEMS LIMITED | 18. Juni 1993 | 18. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HYDROFORD SERVICES LIMITED | 18. Juni 1993 | 18. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEALERSENSE LIMITED | 02. Juni 1993 | 18. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PJ MUSGRAVE ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 18. Juni 1993 | 18. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VENTURE ENTERPRISES (UK) LIMITED | 17. Juni 1993 | 17. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANSTON TRUSTEES LIMITED | 11. Juni 1993 | 15. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J. S. BAILEY LIMITED | 14. Juni 1993 | 14. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MONTFORD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 14. Juni 1993 | 14. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLAREMONT (VTE) LIMITED | 13. Apr. 1993 | 14. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FOURWAYS SHEET METAL LIMITED | 11. Juni 1993 | 11. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
OAKDALE LEISURE LIMITED | 11. Juni 1993 | 11. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
KELTIC FUEL OILS LIMITED | 11. Juni 1993 | 11. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PEAK CATERING EQUIPMENT AND DESIGN LIMITED | 02. Apr. 1993 | 11. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRIAR HILL COURT LIMITED | 25. Jan. 1993 | 11. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POWERSPEED LIMITED | 01. Juni 1993 | 08. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EXEGESIS LIMITED | 07. Juni 1993 | 07. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INITIALBREAK LIMITED | 19. Mai 1993 | 03. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WILLOW LODGE MANAGEMENT COMPANY (MANCHESTER) LIMITED | 02. Juni 1993 | 02. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POXON TRANSPORT AND PLANT HIRE LIMITED | 01. Juni 1993 | 01. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHECKOUT MARKETING LIMITED | 28. Mai 1993 | 28. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BUR SERVICES LTD | 19. Apr. 1993 | 27. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DAVID GALLEY LIMITED | 27. Mai 1993 | 27. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D P (UK) LIMITED | 27. Mai 1993 | 27. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BELGRAVE CARPETS LIMITED | 26. Mai 1993 | 26. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SAMUEL HOLDINGS PLC | 08. Sept. 1992 | 26. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GREEN INSULATION UK LTD | 25. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0