BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 112
Unternehmensleiter
| Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Ist Unternehmensleiter | Ja |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 1 |
| Zurückgetreten | 4879 |
| Gesamt | 4881 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| CHECKOUT MARKETING LIMITED | 28. Mai 1993 | 28. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DAVID GALLEY LIMITED | 27. Mai 1993 | 27. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| D P (UK) LIMITED | 27. Mai 1993 | 27. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BELGRAVE CARPETS LIMITED | 26. Mai 1993 | 26. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TENTERDEN RAILWAY EQUIPMENT AND TRACTION COMPANY LIMITED | 26. Mai 1993 | 25. Juni 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| UNIVERSITY OF LEICESTER STUDENTS' UNION TRADING LTD | 26. Mai 1993 | 05. Aug. 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GREEN INSULATION UK LTD | 25. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HEATON DESIGN LIMITED | 24. Mai 1993 | 24. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HEYSHAM BOAT CHARTER SERVICES LIMITED | 21. Mai 1993 | 21. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SWISS INVESTMENT CORPORATION LIMITED | 21. Mai 1993 | 21. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CENTRALSTYLE LIMITED | 20. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRADEWIND DISPLAY LIMITED | 20. Mai 1993 | 20. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INITIALBREAK LIMITED | 19. Mai 1993 | 03. Juni 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WELCARE GUARDIAN LIMITED | 18. Mai 1993 | 18. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ACTIONVIEW LIMITED | 18. Mai 1993 | 24. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRADELEY MEATS LIMITED | 18. Mai 1993 | 18. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHEADLE HULME DEVELOPMENTS LIMITED | 17. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PROJECT CENTRAL LTD | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JAMES BARKER BELL LIMITED | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AVERY MAGNAY ESTATES LIMITED | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BLOOD AND FIRE LIMITED | 13. Mai 1993 | 13. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RMP HOLDINGS LIMITED | 12. Mai 1993 | 12. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CORPORATE FLEET CARE LIMITED | 11. Mai 1993 | 11. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TYLER AND CO (ARCHITECTS) LIMITED | 11. Mai 1993 | 11. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AIR DISPERSIONS LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHESTER STREET LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RICE INVESTMENTS LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HARTFIELD ESTATES LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WOODS WASTE LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INTERNATIONAL DESIGN AND INVESTMENT LIMITED | 06. Mai 1993 | 10. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PRISCUM LIMITED | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NOJAB LTD | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GLOSSOPDALE BUS COMPANY LIMITED | 05. Mai 1993 | 05. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| REGENT TAVERNS LIMITED | 05. Mai 1993 | 05. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SOYA INTERNATIONAL LIMITED | 30. Apr. 1993 | 30. Apr. 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0