BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Seite 113
Unternehmensleiter
Name | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 4879 |
Gesamt | 4881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
CENTRALSTYLE LIMITED | 20. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHEADLE HULME DEVELOPMENTS LIMITED | 17. Mai 1993 | 25. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HEATON DESIGN LIMITED | 24. Mai 1993 | 24. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SABER SYSTEMS LIMITED | 14. Apr. 1993 | 24. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIONVIEW LIMITED | 18. Mai 1993 | 24. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SWISS INVESTMENT CORPORATION LIMITED | 21. Mai 1993 | 21. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HEYSHAM BOAT CHARTER SERVICES LIMITED | 21. Mai 1993 | 21. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TRADEWIND DISPLAY LIMITED | 20. Mai 1993 | 20. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WELCARE GUARDIAN LIMITED | 18. Mai 1993 | 18. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LILLIE LIMITED | 18. Mai 1992 | 18. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRADELEY MEATS LIMITED | 18. Mai 1993 | 18. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TEAM SPORTS INTERNATIONAL TRAVEL LIMITED | 05. März 1993 | 18. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PROJECT CENTRAL LTD | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AVERY MAGNAY ESTATES LIMITED | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
JAMES BARKER BELL LIMITED | 17. Mai 1993 | 17. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BLOOD AND FIRE LIMITED | 13. Mai 1993 | 13. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RMP HOLDINGS LIMITED | 12. Mai 1993 | 12. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CORPORATE FLEET CARE LIMITED | 11. Mai 1993 | 11. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TYLER AND CO (ARCHITECTS) LIMITED | 11. Mai 1993 | 11. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INTERNATIONAL DESIGN AND INVESTMENT LIMITED | 06. Mai 1993 | 10. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BFPP HOLDINGS LIMITED | 08. Mai 1991 | 08. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HARTFIELD ESTATES LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WOODS WASTE LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
AIR DISPERSIONS LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHESTER STREET LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RICE INVESTMENTS LIMITED | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PRISCUM LIMITED | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
NOJAB LTD | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GLOSSOPDALE BUS COMPANY LIMITED | 05. Mai 1993 | 05. Mai 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REGENT TAVERNS LIMITED | 05. Mai 1993 | 05. Mai 1993 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FLUENTREACH LIMITED | 02. Mai 1991 | 02. Mai 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SOYA INTERNATIONAL LIMITED | 30. Apr. 1993 | 30. Apr. 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BILFORGE (1990) LIMITED | 30. Apr. 1993 | 30. Apr. 1993 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
REGAL FISH SUPPLIES LIMITED | 28. Apr. 1993 | 28. Apr. 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
EPIGRAM COMMUNICATIONS AND DESIGN LIMITED | 27. Apr. 1993 | 27. Apr. 1993 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0